Dirigenza

Dirigenza attuale

Persona Network Funzione Modalità di firma Dal Per
delegato del consiglio d'amministrazione firma collettiva a due 13.03.2017
presidente del consiglio d'amministrazione firma collettiva a due 13.03.2017
membro del consiglio d'amministrazione firma collettiva a due 13.03.2017

Dirigenza precedente

1 ulteriore voce
Visibile con registrazione
Si registri gratuitamente
Dati di base
Società anonima
CHF 2’182’000
Ultimo cambiamento: 05.05.2021

Sede

Altnau (TG)

Scopo

Die Gesellschaft bezweckt die ganze oder teilweise Beteiligung an oder Finanzierung von Finanz-, Industrie-, Handels- oder anderen Unternehmen im Bereich neuer Verfahrenstechniken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mostra di più

IDI

CHE-101.749.495

Numero d'ordine

CH-217.0.136.804-4

Registro di commercio

Cantone Turgovia

Estratto del registro di commercio

Ragioni sociali precedenti

Quartiere

Imprese nel quartiere

8 imprese con lo stesso domicilio: Moosgrabenstrasse 12, 8595 Altnau

Informazioni
Lixt Betreibungsauszug

Estratto del registro esecuzioni

Controlli la dichiarazione di recupero crediti prima di concludere un contratto.

Lixt Bonitätsauskunft

Informazione di solvibilità

Controlli la solvibilità dei suoi prospetti e clienti.

Lixt Handelsregisterauszug

Estratto del registro di commercio

Consulti l'estratto attuale del registro commerciale online.

Pubblicazioni

Pubblicazioni

1 - 13 su 13

FUSC05.05.2021
|
FÜLL PROCESS S.A.

Mutazione FÜLL PROCESS S.A.

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

FÜLL PROCESS S.A., in Altnau, CHE-101.749.495, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2019, Publ. 1004731769).

Statutenänderung:
08.04.2021. 16.04.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 2'182'000.00 [bisher: CHF 1'682'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'182'000.00 [bisher: CHF 1'682'000.00].

Aktien neu:
2'182 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'682 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 16.04.2021 wird eine Forderung im Betrag von CHF 500'000.00 verrechnet, wofür 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 zugeteilt werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen per Einschreiben oder per E-Mail.

FUSC: 86 del 05.05.2021
Registro giornaliero: 2399 del 30.04.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005170160
Cantoni: TG

FUSC07.10.2019
|
FÜLL PROCESS S.A.

Mutazione FÜLL PROCESS S.A.

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

FÜLL PROCESS S.A., in Altnau, CHE-101.749.495, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2017, Publ. 3407941).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zähner, Pierre Willy, von Hundwil, in Longirod, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 193 del 07.10.2019
Registro giornaliero: 4620 del 02.10.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004731769
Cantoni: TG

FUSC16.03.2017
|
FÜLL PROCESS S.A.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo

FÜLL PROCESS S.A., bisher in Fribourg, CHE-101.749.495, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2016, Publ. 2908435).

Statutenänderung:
03.03.2017.

Sitz neu:
Altnau.

Domizil neu:
Moosgrabenstrasse 12, 8595 Altnau.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die ganze oder teilweise Beteiligung an oder Finanzierung von Finanz-, Industrie-, Handels- oder anderen Unternehmen im Bereich neuer Verfahrenstechniken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Registro giornaliero no 1207 del 13.03.2017 / CHE-101.749.495 / 03407941

FUSC16.03.2017
|
FÜLL PROCESS S.A.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

FÜLL PROCESS S.A., in Fribourg, CHE-101.749.495 (FOSC du 23.06.2016, p. 0/2908435). Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Altnau.

Registro giornaliero no 2267 del 13.03.2017 / CHE-101.749.495 / 03407601

FUSC23.06.2016
|
FÜLL PROCESS S.A.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

FÜLL PROCESS S.A., à Fribourg, CHE-101.749.495 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826).

Augmentation ordinaire:
Capital-actions porté de CHF 810'000 à CHF 1'682'000 par l'émission de 872 actions de CHF 1'000, au porteur, entièrement libérées par apport en nature: Selon contrat d'apport du 14.06.2016, par 3'000 actions de CHF 100, nominatives et liées selon les statuts, de Tecos Bruhin AG (CHE-470.634.152), à Altnau, pour le prix de CHF 872'000. Statuts modifiés le 14.06.2016.

Capital-actions actuel:
CHF 1'682'000, entièrement libéré, divisé en 1'682 actions de CHF 1'000, au porteur. Hafner Luc n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Eichenberger Nicolas, administrateur délégué, nom précis Eichenberger Nicolas Philippe Maurice, maintenant à Mies, maintenant administrateur et président, avec signature collective à deux. Zähner Pierre, administrateur président, nom précis Zähner Pierre Willy, maintenant à Longirod et administrateur vice-président, avec signature collective à deux. Bruhin Cornelius Alois, de Schübelbach, à Weinfelden, nommé administrateur et gérant, Sauter Niklaus, d'Ermatingen, à Weinfelden, nommé administrateur, tous deux avec signature collective à deux.

Registro giornaliero no 4022 del 20.06.2016 / CHE-101.749.495 / 02908435

FUSC06.11.2009
|
FÜLL PROCESS S.A.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FÜLL PROCESS S.A., à Fribourg, CH-217-0136804-4, participer ou financer toutes entreprises financières, industrielles, etc. (FOSC du 06.05.2008, p. 7). Statuts modifiés le 22.09.2009. Selon déclaration du 22.09.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. Ofisa n'est plus organe de révision.

Tagebuch Nr. 5940 vom 02.11.2009
(05331788/CH21701368044)

FUSC06.05.2008
|
FÜLL PROCESS S.A.

Grund: Handelsregister (Mutationen)

FÜLL PROCESS S.A., à Fribourg, CH-217-0136804-4, participer ou financer toutes entreprises financières, industrielles, etc. (FOSC du 12.02.2008, p. 7).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Cynova SA, à Fribourg (CH-217-0136822-7), selon contrat de fusion du 25.04.2008 et bilan au 01.04.2008, présentant des actifs de CHF 107'936.99, des passifs envers les tiers de CHF 9'791.84, soit un actif net de CHF 98'145.15. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Tagebuch Nr. 1622 vom 29.04.2008
(04463124/CH21701368044)

FUSC02.05.2008
|
FÜLL PROCESS S.A.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Kapital neu

Hopare Holding SA, à Fribourg, CH-217-0136804-4, participer ou financer toutes entreprises financières, industrielles, etc. (FOSC du 12.02.2008, p. 7).

Nouvelle raison sociale:
FÜLL PROCESS S.A.[FÜLL PROCESS AG] [FÜLL PROCESS , Inc.] [FÜLL PROCESS LTD] [FÜLL PROCESS S.p.a.] [FÜLL PROCESS K.K.] [FÜLL PROCESS AB] [FÜLL PROCESS A/S] [FÜLL PROCESS N.V.]. Capital-actions réduit au sens de l'art. 735 CO de CHF 2'250'000.-- à CHF 810'000.--.-- par destruction de 1'440 actions de CHF 1'000.--, au porteur.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée. Statuts modifiés le 14.04.2008.

Capital-actions actuel:
CHF 810'000.--, entièrement libéré, divisé en 810 actions de CHF 1'000.--, au porteur.

Tagebuch Nr. 1567 vom 25.04.2008
(04457530/CH21701368044)

FUSC12.02.2008
|
Hopare Holding SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Hopare Holding SA, à Fribourg, CH-217-0136804-4, participer ou financer toutes entreprises financières, etc. (FOSC du 15.06.2007, p. 6).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de BLANC-INDIM SA, à Yverdon-les-Bains (CH-550-0158980-7), selon contrat de fusion du 29.01.2008 et bilan au 31.10.2007, présentant des actifs de CHF 948'141.06, des passifs envers les tiers de CHF 436'048.60, soit un actif net de CHF 512'092.46. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Tagebuch Nr. 458 vom 06.02.2008
(04335432/CH21701368044)

FUSC15.06.2007
|
Hopare Holding SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hopare Holding SA, à Fribourg, CH-217-0136804-4, participer ou financer toutes entreprises financières, industrielles, etc. (FOSC du 01.05.2007, p. 7). Kesselman Joseph I., administrateur, a démissionné, sa signature est radiée.

Tagebuch Nr. 2524 vom 11.06.2007
(03976314/CH21701368044)

FUSC01.05.2007
|
Hopare Holding SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Hopare Holding SA, à Fribourg, CH-217-0136804-4, participer ou financer toutes entreprises financières, industrielles, etc. (FOSC du 16.06.2005, p. 7). Capital-actions réduit au sens de l'art. 735 CO de CHF 4'250'000.-- à CHF 1'250'000.-- par cancellation de 3'000 actions de CHF 1'000.--, au porteur. Capital-actions porté de CHF 1'250'000.-- à CHF 2'250'000.-- par l'émission de 1'000 actions de CHF 1'000.--, au porteur, entièrement libéré par compensation de créance. Statuts modifiés le 18.04.2007.

Capital-actions actuel:
CHF 2'250'000.--, entièrement libéré, divisé en 2'250 actions de CHF 1'000.--, au porteur.

Tagebuch Nr. 1882 vom 25.04.2007
(03909660/CH21701368044)

FUSC16.06.2005
|
Hopare Holding SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hopare Holding SA, à Fribourg, CH-217-0136804-4, participer ou financer toutes entreprises financières, etc. (FOSC du 05.10.2004, p. 6). Société Roger Peyraud n'est plus réviseur.

Nouveau réviseur:
Ofisa, à Lausanne.

Tagebuch Nr. 2515 vom 10.06.2005
(02885780/CH21701368044)

FUSC05.10.2004
|
Hopare Holding SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Hopare Holding SA, à Fribourg, participer ou financer toutes entreprises financières, industrielles, commerciales ou autres dans le domaine des techniques de procédés nouveaux. (FOSC du 01.12.2000, p. 8203).

Nouvelle adresse:
Place de Notre-Dame 4, c/o Me Jean-Pierre Wolhauser. Capital-actions porté de CHF 500'000.-- à CHF 4'250'000.-- par l'émission de 3'750 actions de CHF 1'000.--, au porteur, entièrement libérées par compensation de créance. Statuts modifiés le 17.09.2004.

Capital-actions actuel:
CHF 4'250'000.--, entièrement libéré, divisé en 4'250 actions de CHF 1'000.--, au porteur.

Tagebuch Nr. 4235 vom 29.09.2004
(02477760/CH21701368044)

I nostri prodotti
Lixt Monitoring Lixt Monitoring

Monitoring

Sta cercando informazioni su aziende, management, commesse e marchi? Ora è gratuito.
Lixt Recupero Crediti Lixt Recupero Crediti

Recupero Crediti

I suoi clienti non pagano le fatture? La aiuteremo a recuperare il suo denaro.
Lixt Factoring Lixt Factoring

Factoring

Soffre di lunghi periodi di pagamento? Paghiamo le fatture dei suoi clienti entro 2 giorni.
Lixt
Gratuito

Pacchetto iniziale Lixt

Include l'accesso a tutte le informazioni di base, ai marchi e a 2 sorveglianze.

Si registri gratuitamente