Management

Aktuelles Management

Person Netzwerk Funktion Unterschrift Seit Bis
Kollektivunterschrift zu 2 28.12.2018
Revisionsstelle 01.02.2019
Präsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu 2 26.09.2018
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu 2 11.04.2019
Vizepräsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu 2 11.04.2019
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu 2 11.04.2019
Kollektivunterschrift zu 2 11.04.2019
Kollektivunterschrift zu 2 28.12.2018
Kollektivunterschrift zu 2 11.04.2019
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu 2 11.04.2019
Kollektivunterschrift zu 2 11.04.2019
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu 2 11.04.2019
Kollektivunterschrift zu 2 11.04.2019
Direktor Kollektivunterschrift zu 2 11.04.2019
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu 2 11.04.2019
sec. hors cons. Kollektivunterschrift zu 2 11.04.2019
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu 2 11.04.2019
Kollektivunterschrift zu 2 29.08.2019
Direktor Kollektivunterschrift zu 2 29.08.2019
Kollektivunterschrift zu 2 11.04.2019
Kollektivunterschrift zu 2 23.04.2020
Kollektivunterschrift zu 2 28.12.2018
Kollektivunterschrift zu 2 11.04.2019
Direktor Kollektivunterschrift zu 2 11.04.2019
Direktor Kollektivunterschrift zu 2 29.08.2019
adm. Président de la direction / CEO Kollektivunterschrift zu 2 11.04.2019
Direktorin Kollektivunterschrift zu 2 24.02.2022
Kollektivunterschrift zu 2 24.02.2022
Kollektivunterschrift zu 2 24.02.2022
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu 2 16.05.2022
Kollektivunterschrift zu 2 08.03.2023
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu 2 11.04.2019
Kollektivunterschrift zu 2 23.04.2020
Kollektivunterschrift zu 2 28.12.2018

Früheres Management

20 weitere Einträge
Mit Registrierung sichtbar
Kostenlos registrieren
Stammdaten
Aktiengesellschaft
21.09.2018
CHF 19’988’000
Letzte Änderung: 25.01.2024

Sitz

Fribourg (FR)

Zweck

La Société a pour but d'acquérir, de détenir, de gérer, et d'aliéner des participations directes et indirectes dans des entreprises de toute nature, en particulier des entreprises actives dans le domaine de la santé, des équipements médicaux, de la biologie, la chimie, la physique, de l'informatique ou d'autres domaines liés, en Suisse ou à l'étranger. La Société peut constituer des entreprises de toute nature en Suisse ou à l'étranger, détenir des parts dans ces entreprises et en assumer la gestion. La Société peut aquérir, mettre en gage, exploiter et aliéner des immeubles et des droits immatiériels en Suisse et à l'étranger. La Société peut accorder des prêts, des garanties et toutes autres sortes de financements ou de sûretés pour des sociétés du Groupe, ainsi qu'emprunter et investir des fonds dans les marchés des devises et des capitaux. La Société peut s'engager dans des activités ou des transactions de toute autre nature et peut prendre toutes mesures qui lui apparaissent adéquates à promouvoir le but de la Société ou qui sont liées à celui-ci. Dans la poursuite de son but, la Société aspire à la création de valeur durable. Mehr anzeigen

UID

CHE-234.781.164

CH-Nummer

CH-217.3.568.146-7

Handelsregisteramt

Kanton Freiburg

Handelsregisterauszug

Nachbarschaft

Firmen in der Nachbarschaft

2 Firmen mit gleichem Domizil: Rue Louis-d'Affry 6, 1701 Fribourg

Auskünfte
Lixt Betreibungsauszug

Betreibungsauszug

Prüfen Sie vor Vertragsabschluss den Betreibungsauszug Ihrer Interessenten.

Lixt Bonitätsauskunft

Bonitätsauskunft

Prüfen Sie die Zahlungsfähigkeit Ihrer Interessenten und Kunden.

Lixt Handelsregisterauszug

Handelsregisterauszug

Sehen Sie sich den aktuellen Auszug aus dem Handelsregister online an.

Publikationen

Publikationen

1 - 20 von 21

SHAB08.04.2024
|
Alcon AG

Einladung zur Generalversammlung Alcon AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

Alcon AG
Rue Louis-d'Affry 6
1701 Fribourg

Angaben zur Generalversammlung
08.05.2024, 09:30 Uhr
SwissTech Convention Center (STCC),
Rue Louis Favre 2,
1024 Ecublens,
Switzerland
(doors open at 08:30 a.m. CEST)

Traktanden

1. Approval of the operating and financial review of Alcon Inc., the annual financial statements of Alcon Inc. and the consolidated financial statements for 2023

2. Discharge of the members of the Board of Directors and the members of the Executive Committee

3.    Appropriation of earnings and declaration of dividend as per the balance sheet of Alcon Inc. of December 31, 2023

4.    Consultative vote on the 2023 Report on Non-Financial Matters

5.    Votes on the compensation of the Board of Directors and of the Executive Committee
5.1    Consultative vote on the 2023 Compensation Report
5.2    Binding vote on the maximum aggregate amount of compensation of the Board of Directors for the next term of office, i.e. from the 2024 Annual General Meeting to the 2025 Annual General Meeting
5.3    Binding vote on the maximum aggregate amount of compensation of the Executive Committee for the following financial year, i.e. 2025

6.    Re-elections of the Chair and the Members of the Board of Directors
6.1    Re-election of F. Michael Ball (as Member and Chair)
6.2    Re-election of Lynn D. Bleil (as Member)
6.3    Re-election of Raquel C. Bono (as Member)
6.4    Re-election of Arthur Cummings (as Member)
6.5    Re-election of David J. Endicott (as Member)
6.6    Re-election of Thomas Glanzmann (as Member)
6.7    Re-election of D. Keith Grossman (as Member)
6.8    Re-election of Scott Maw (as Member)
6.9    Re-election of Karen May (as Member)
6.10 Re-election of Ines Pöschel (as Member)
6.11 Re-election of Dieter Spälti (as Member)

7.    Re-elections of the Members of the Compensation Committee
7.1    Re-election of Thomas Glanzmann
7.2    Re-election of Scott Maw
7.3    Re-election of Karen May
7.4    Re-election of Ines Pöschel

8.    Re-election of the independent representative

9.    Re-election of the statutory auditors



SHAB: 67 vom 08.04.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005893
Meldestelle: Homburger AG
Kantone: ZH, FR
SHAB25.01.2024
|
Alcon AG

Mutation Alcon AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Alcon AG, à Fribourg, CHE-234.781.164 (FOSC du 12.05.2023, p. 0/1005745071).

Personne inscrite modifiée:
Pöschel Ines, administratrice, signature collective à deux, maintenant à Cham.

SHAB: 17 vom 25.01.2024
Tagesregister: 592 vom 22.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005943881
Kantone: FR

SHAB12.05.2023
|
Alcon AG

Mutation Alcon AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Alcon AG, à Fribourg, CHE-234.781.164 (FOSC du 16.05.2022, p. 0/1005474303). Statuts modifiés le 05.05.2023. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 29.01.2019), le délai étant écoulé. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 05.05.2023; pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 05.05.2023; pour les détails, voir les statuts.

Communication aux actionnaires:
FOSC, par courrier, e-mail ou toute autre forme permettant d'en établir la preuve par texte, aux dernières coordonnées enregistrées de l'actionnaire ou de son bénéficiaire autorisé.

SHAB: 92 vom 12.05.2023
Tagesregister: 3183 vom 10.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005745071
Kantone: FR

SHAB30.03.2023
|
Alcon AG

Einladung zur Generalversammlung Alcon AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

Alcon AG
Rue Louis-d'Affry 6
1701 Fribourg

Angaben zur Generalversammlung
05.05.2023, 09:30 Uhr
SwissTech Convention Center (STCC)
Rue Louis Favre 2
1024 Ecublens
Switzerland
(doors open at 08:30 a.m. CEST)

Traktanden

1. Approval of the operating and financial review of Alcon Inc., the annual financial statements of Alcon Inc. and the consolidated financial statements for 2022

2. Discharge of the members of the Board of Directors and the members of the Executive Committee

3. Appropriation of earnings and declaration of dividend as per the balance sheet of Alcon Inc. of December 31, 2022

4. Votes on the compensation of the Board of Directors and of the Executive Committee

4.1 Consultative vote on the 2022 Compensation Report

4.2 Binding vote on the maximum aggregate amount of      compensation of the Board of Directors for the next term of office,  i.e. from the 2023 Annual General Meeting to the 2024 Annual General Meeting

4.3 Binding vote on the maximum aggregate amount of compensation of the Executive Committee for the following financial year, i.e. 2024

5. Re-elections of the Chair and the Members of the Board of Directors

5.1 Re-election of F. Michael Ball (as Member and Chair)

5.2 Re-election of Lynn D. Bleil (as Member)

5.3 Re-election of Raquel C. Bono (as Member)

5.4 Re-election of Arthur Cummings (as Member)

5.5 Re-election of David J. Endicott (as Member)

5.6 Re-election of Thomas Glanzmann (as Member)

5.7 Re-election of D. Keith Grossman (as Member)

5.8 Re-election of Scott Maw (as Member)

5.9 Re-election of Karen May (as Member)

5.10 Re-election of Ines Pöschel (as Member)

5.11 Re-election of Dieter Spälti (as Member)

6. Re-elections of the members of the Compensation Committee

6.1 Re-election of Thomas Glanzmann

6.2 Re-election of Scott Maw

6.3 Re-election of Karen May

6.4 Re-election of Ines Pöschel

7. Re-election of the independent representative

8. Re-election of the statutory auditors

9. Amendments to the Articles of Incorporation

9.1 Deletion of the current Article 4a and introduction of a capital range (new Article 4a)

9.2 Introduction of a conditional share capital (new Article 4b)

9.3 Share capital (Article 4 and new Article 4c)

9.4 Shareholders matters (Article 9, Article 10 paragraph 2, Article 11 paragraph 1, Article 12, Article 17, Article 18 and Article 38) 

9.5 Board of Directors and related topics (Article 22 and Article 24 paragraph 1)

9.6 Compensation and related topics (Article 29 paragraph 4, Article 30, Article 33 and Article 34 paragraph 3 and paragraph 4)

Fribourg, March 30, 2023
Alcon Inc.
Board of Directors






SHAB: 63 vom 30.03.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004890
Meldestelle: Homburger AG
Kantone: ZH, FR
SHAB08.03.2023
|
Alcon AG

Mutation Alcon AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Alcon AG, à Fribourg, CHE-234.781.164 (FOSC du 16.05.2022, p. 0/1005474303).

Nouvelle personne inscrite:
Hart Lisa Marie, des Etats-Unis, à Genève, signature collective à deux.

SHAB: 47 vom 08.03.2023
Tagesregister: 1672 vom 03.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005695617
Kantone: FR

SHAB16.05.2022
|
Alcon AG

Mutation Alcon AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Alcon AG, à Fribourg, CHE-234.781.164 (FOSC du 24.02.2022, p. 0/1005413486).

Personne radiée:
McCracken Merrick, signature collective à deux.

Nouvelle personne inscrite:
Bono Raquel Cruz, des Etats-Unis, à San Antonio (US), administratrice, signature collective à deux.

SHAB: 94 vom 16.05.2022
Tagesregister: 2956 vom 11.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005474303
Kantone: FR

SHAB24.03.2022
|
Alcon AG

Einladung zur Generalversammlung Alcon AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

Alcon AG
Rue Louis-d'Affry 6
1701 Fribourg

Angaben zur Generalversammlung
27.04.2022, 10:00 Uhr
Avenue d'Ouchy 40
1006 Lausanne

Traktanden

Invitation/Agenda:

1.     Approval of the operating and financial review of Alcon Inc., the annual financial statements of Alcon Inc. and the consolidated financial statements for 2021

2.     Discharge of the members of the Board of Directors and the members of the Executive Committee

3.     Appropriation of earnings and declaration of dividend as per the balance sheet of Alcon Inc. of December 31, 2021

4.     Votes on the compensation of the Board of Directors and of the Executive Committee

4.1 Consultative vote on the 2021 Compensation Report

4.2 Binding vote on the maximum aggregate amount of compensation of the Board of Directors for the next term of office, i.e. from the 2022 Annual General Meeting to the 2023 Annual General Meeting

4.3 Binding vote on the maximum aggregate amount of compensation of the Executive Committee for the following financial year, i.e. 2023

5.     Re-election and election of the Chair and the Members of the Board of Directors

5.1 Re-election of F. Michael Ball (as Member and Chair)

5.2 Re-election of Lynn D. Bleil (as Member)

5.3 Re-election of Arthur Cummings (as Member)

5.4 Re-election of David J. Endicott (as Member)

5.5 Re-election of Thomas Glanzmann (as Member)

5.6 Re-election of D. Keith Grossman (as Member)

5.7 Re-election of Scott Maw (as Member)

5.8 Re-election of Karen May (as Member)

5.9 Re-election of Ines Pöschel (as Member)

5.10 Re-election of Dieter Spälti (as Member)

5.11 Election of Raquel C. Bono (as Member)

6.     Re-election and election of the members of the Compensation Committee

            6.1 Re-election of Thomas Glanzmann

            6.2 Re-election of Karen May

            6.3 Re-election of Ines Pöschel

            6.4 Election of Scott Maw

7.     Re-election of the independent representative

8.     Re-election of the statutory auditors


IMPORTANT INFORMATION RELATING TO THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING

As a result of the continuing tense situation due to the coronavirus (COVID-19) pandemic, and as a precautionary and prudent measure, the Board of Directors decided that the 2022 Annual General Meeting will again be held without the personal attendance of shareholders and you will not be granted access to the meeting room, in accordance with the Federal Act on the statutory principles for Federal Council Ordinances on combating the COVID-19 epidemic and the Ordinance 3 of the Swiss Federal Council regarding measures to combat the COVID-19, both as amended (COVID-19 Regulations).

Accordingly, and in accordance with the COVID-19 Regulations, shareholders shall exercise their rights at our Annual General Meeting exclusively by sending in voting instructions to the independent representative identified in the voting materials. For information on how to issue your voting instructions to the independent representative, please refer to the "Organizational topics" at the end of the Annual General Meeting invitation.

We take the safety of our shareholders, directors, officers, associates and service providers very seriously. We hope that you understand the need to take these extraordinary measures and look forward to your participation in person at the 2023 Annual General Meeting.



SHAB: 59 vom 24.03.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003977
Meldestelle: Homburger AG
Kantone: ZH, FR
SHAB24.02.2022
|
Alcon AG

Mutation Alcon AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Alcon AG, à Fribourg, CHE-234.781.164 (FOSC du 07.12.2020, p. 0/1005040740).

Personnes radiées:
Onuscheck John Michael, directeur, signature collective à deux; Auffret Sandrine Laurence, signature collective à deux; Eaton John Butler, signature collective à deux; Hjalber Jan Olof, signature collective à deux; Russell Dominic James, signature collective à deux; Scholtz Duncan Myndert Lacock, signature collective à deux; Westermann Michael, signature collective à deux.

Personne inscrite modifiée:
Guertin Marie-Claude, signature collective à deux, maintenant à Neyruz FR.

Nouvelles personnes inscrites:
Lin Sue Jean, du Royaume-Uni, à Pregny-Chambésy, directrice, signature collective à deux; Brilis Dimitrios, de Grèce, à Riehen, signature collective à deux; Dailey Kerry Haydel, des Etats-Unis, à Founex, signature collective à deux.

SHAB: 39 vom 24.02.2022
Tagesregister: 1153 vom 21.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005413486
Kantone: FR

SHAB25.03.2021
|
Alcon AG

Einladung zur Generalversammlung Alcon AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

Alcon AG
Rue Louis-d'Affry 6
1701 Fribourg

Angaben zur Generalversammlung
28.04.2021, 10:00 Uhr
Rue Louis-d'Affry 6
1701 Fribourg

Traktanden
  1. Approval of the operating and financial review of Alcon Inc., the annual financial statements of Alcon Inc. and the consolidated financial statements for 2020
  2. Discharge of the members of the Board of Directors and the members of the Executive Committee
  3. Appropriation of earnings and declaration of dividend as per the balance sheet of Alcon Inc. of December 31, 2020
  4. Votes on the compensation of the Board of Directors and of the Executive Committee
    4.1 Consultative vote on the 2020 Compensation Report
    4.2 Binding vote on the maximum aggregate amount of compensation of the Board of Directors for the next term of office, i.e. from the 2021 Annual General Meeting to the 2022 Annual General Meeting
    4.3 Binding vote on the maximum aggregate amount of compensation of the Executive Committee for the following financial year, i.e. 2022
  5. Re-election of the Chair and the Members of the Board of Directors
    5.1 Re-election of F. Michael Ball (as Member and Chair)
    5.2 Re-election of Lynn D. Bleil (as Member)
    5.3 Re-election of Arthur Cummings (as Member)
    5.4 Re-election of David J. Endicott (as Member)
    5.5 Re-election of Thomas Glanzmann (as Member)
    5.6 Re-election of D. Keith Grossman (as Member)
    5.7 Re-election of Scott Maw (as Member)
    5.8 Re-election of Karen May (as Member)
    5.9 Re-election of Ines Pöschel (as Member)
    5.10 Re-election of Dieter Spälti (as Member)
  6. Re-election of the members of the Compensation Committee
    6.1 Re-election of Thomas Glanzmann
    6.2 Re-election of D. Keith Grossman
    6.3 Re-election of Karen May
    6.4 Re-election of Ines Pöschel
  7. Re-election of the independent representative
  8. Re-election of the statutory auditors

Fribourg, March 25, 2021

Alcon Inc.

Board of Directors


IMPORTANT INFORMATION RELATING TO COVID-19 PANDEMIC

As a result of the continuing exceptional circumstances due to the coronavirus (COVID-19) pandemic, the 2021 Annual General Meeting will be held without the personal attendance of shareholders and you will not be granted access to the meeting room, in accordance with the Ordinance of the Swiss Federal Council regarding measures on combating the coronavirus (COVID-19) as amended on March 1, 2021 (COVID-19 Ordinance 3).

Accordingly, and in accordance with the COVID-19 Ordinance 3, shareholders shall exercise their rights at our Annual General Meeting exclusively by sending in voting instructions to the independent representative identified in the voting materials. For information on how to issue your voting instructions to the independent representative please refer to the Organizational topics" at the end of the attached invitation.



SHAB: 59 vom 25.03.2021
Meldungsnummer: UP04-0000002872
Meldestelle: Homburger AG
Kantone: ZH, FR
SHAB07.12.2020
|
Alcon AG

Mutation Alcon AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Alcon AG, à Fribourg, CHE-234.781.164 (FOSC du 23.04.2020, p. 0/1004875897). Augmentation autorisée fondée sur la décision d'autorisation du 29.01.2019.

Capital-actions nouveau:
19'988'000, entièrement libéré, divisé en 499'700'000 actions nominatives de CHF 0.04. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 29.01.2019), par décision du 01.12.2020, pour le détail cf. statuts. Statuts modifiés le 01.12.2020.

SHAB: 238 vom 07.12.2020
Tagesregister: 6799 vom 02.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005040740
Kantone: FR

SHAB23.04.2020
|
Alcon AG

Mutation Alcon AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Alcon AG, à Fribourg, CHE-234.781.164 (FOSC du 05.12.2019, p. 0/1004775695).

Personnes radiées:
Colombo Franco, signature collective à deux; Lutz Manuel Hubertus Maria Felix, signature collective à deux; Saiz Garcia Maria, signature collective à deux.

Personnes inscrites modifiées:
Attias Laurent, directeur, signature collective à deux, maintenant à Genève; Bohmann Christine, signature collective à deux, maintenant à Arzier-Le Muids; Kamffer Robert Edward, signature collective à deux, maintenant à Hauterive FR; Russell Dominic James, signature collective à deux, maintenant à Genève.

Nouvelles personnes inscrites:
Chapuis Alexis Aubry Hugues Marie Léopold, de France, à Genève, signature collective à deux; Eaton John Butler, des Etats-Unis, à Genève, signature collective à deux; Westermann Michael, de et à Tafers, signature collective à deux; Vocat Xavier François, de Chalais, à Lausanne, signature collective à deux.

SHAB: 78 vom 23.04.2020
Tagesregister: 2291 vom 20.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004875897
Kantone: FR

SHAB02.04.2020
|
Alcon AG

Einladung zur Generalversammlung Alcon AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

Alcon AG
Rue Louis-d'Affry 6
1701 Fribourg

Angaben zur Generalversammlung
06.05.2020, 10:00 Uhr
Forum Fribourg
Route du Lac 12
1763 Granges-Paccot/Fribourg
Switzerland

Traktanden

Agenda

  1. Approval of the operating and financial review of Alcon Inc., the annual financial statements of Alcon Inc. and the consolidated financial statements for 2019.
  2. Discharge of the members of the Board of Directors and the members of the Executive Committee
  3. Appropriation of earnings and declaration of dividend as per the balance sheet of Alcon Inc. of December 31, 2019
  4. Votes on the compensation of the Board of Directors and of the Executive Committee
    4.1.Consultative vote on the 2019 Compensation Report
    4.2. Binding vote on the maximum aggregate amount of compensation of the Board of Directors for the next term of office, i.e. from the 2020 Annual General Meeting to the 2021 Annual General Meeting
    4.3.Binding vote on the maximum aggregate amount of compensation of the Executive Committee for the following financial year, i.e. 2021
  5. Re-elections of the Chair and the Members of the Board of Directors
    5.1. Re-election of F. Michael Ball (as Member and Chair)
    5.2. Re-election of Lynn D. Bleil (as Member)
    5.3. Re-election of Arthur Cummings, M.D. (as Member)
    5.4.Re-election of David J. Endicott (as Member)
    5.5.Re-election of Thomas Glanzmann (as Member)
    5.6. Re-election of D. Keith Grossman (as Member)
    5.7. Re-election of Scott Maw (as Member)
    5.8. Re-election of Karen May (as Member)
    5.9. Re-election of Ines Pöschel (as Member)
    5.10. Re-election of Dieter Spälti, Ph.D. (as Member)
  6. Re-elections of the members of the Compensation Committee
    6.1. Re-election of Thomas Glanzmann
    6.2. Re-election of D. Keith Grossman
    6.3. Re-election of Karen May
    6.4. Re-election of Ines Pöschel
  7. Re-election of the independent representative
  8. Re-election of the statutory auditors

Fribourg, April 2, 2020

Alcon Inc.

Board of Directors



IMPORTANT INFORMATION RELATING TO COVID-19 OUTBREAK

Due to the global coronavirus (COVID-19) outbreak, the Federal Council has categorized the current situation in Switzerland as extraordinary under the terms of the Epidemics Act and, accordingly, has enacted new measures to prevent the spread of the coronavirus under COVID-19 Ordinance 2, as amended on March 16, 2020. Among other measures, the Federal Council has now banned all public and private events in Switzerland and allowed companies to impose on their shareholders the ability to exercise their rights exclusively through voting instructions to the independent proxy.

In accordance with the COVID-19 Ordinance 2, the Board of Directors ordered that all shareholders shall exercise their rights at the Annual General Meeting exclusively by sending in voting instructions to the independent representative, Hartmann Dreyer Attorneys-at-Law. Shareholders will no longer be granted access to the meeting room on the day of the meeting.



SHAB: 65 vom 02.04.2020
Meldungsnummer: UP04-0000001754
Meldestelle: Homburger AG
Kantone: ZH, FR
SHAB05.12.2019
|
Alcon AG

Mutation Alcon AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Alcon AG, à Fribourg, CHE-234.781.164 (FOSC du 03.09.2019, p. 0/1004707932).

Capital-actions nouveau:
CHF 19'668'000, entièrement libéré, divisé en 491'700'000 actions nominatives de CHF 0.04. Augmentation autorisée du capital fondée sur la décision d'autorisation du 29.01.2019. Nouveaux statuts du 29.11.2019.

SHAB: 236 vom 05.12.2019
Tagesregister: 6749 vom 02.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004775695
Kantone: FR

SHAB03.09.2019
|
Alcon AG

Mutation Alcon AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Alcon AG, à Fribourg, CHE-234.781.164 (FOSC du 29.08.2019, p. 0/1004705094). Rectification de l'inscription n° 4690 du 26.08.2019 (FOSC du 29.08.2019, Id 1004705094): Nouvelles personnes inscrites: Stonesifer Timothy Charles, des Etats-Unis, à Fort Worth (US) (et non pas Forth Worth), directeur, signature collective à deux; Buckley Margaret Mary, des Etats-Unis, à Fort Worth (US) (et non pas Forth Worth), signature collective à deux.

SHAB: 169 vom 03.09.2019
Tagesregister: 4799 vom 29.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004707932
Kantone: FR

SHAB29.08.2019
|
Alcon AG

Mutation Alcon AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Alcon AG, à Fribourg, CHE-234.781.164 (FOSC du 17.04.2019, p. 0/1004612683).

Nouvelles personnes inscrites:
Narayanan Rajkumar, des Etats-Unis, à Genève, directeur, signature collective à deux; Stonesifer Timothy Charles, des Etats-Unis, à Forth Worth (US), directeur, signature collective à deux; Buckley Margaret Mary, des Etats-Unis, à Forth Worth (US), signature collective à deux.

SHAB: 166 vom 29.08.2019
Tagesregister: 4690 vom 26.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004705094
Kantone: FR

SHAB17.04.2019
|
Alcon AG

Mutation Alcon AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Alcon AG, à Fribourg, CHE-234.781.164 (FOSC du 11.04.2019, p. 0/1004608462). Rectification de l'inscription n° 2091 du 09.04.2018 (FOSC du 11.04.2019, Id 1004608462): Nouvelle personne inscrite: Baldock Lesley Jane, d'Angleterre, à Genève (et non pas Misery-Courtion), signature collective à deux.

SHAB: 75 vom 17.04.2019
Tagesregister: 2178 vom 12.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004612683
Kantone: FR

SHAB11.04.2019
|
Alcon AG

Mutation Alcon AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Alcon AG, à Fribourg, CHE-234.781.164 (FOSC du 01.02.2019, p. 0/1004556416).

Personnes radiées:
Kirsch Harry Werner, administrateur président, signature collective à deux. Klinger Shannon Thyme, administrateur secrétaire, signature collective à deux. Baert Steven Lodewijk Margareta, administrateur, signature collective à deux. Eichhorn Felix Hermann, signature collective à deux. Rehm Christian Jakob, signature collective à deux. Roth Pellanda Katja Nicole, signature collective à deux. Schreiner Peter Christian, signature collective à deux. Weiss Daniel Andreas, signature collective à deux.

Personnes inscrites modifiées:
Ball Francis Michael, administrateur, signature collective à deux, maintenant administrateur, président, signature collective à deux.

Nouvelles personnes inscrites:
Grossman Donald Keith, des Etats-Unis, à Diablo (US), administrateur, vice-président, signature collective à deux. Bleil Lynn Dorsey, des Etats-Unis, à Park City (US), administrateur, signature collective à deux. Cummings Arthur Bernard, d'Irlande, à Dublin (IE), administrateur, signature collective à deux. Endicott David John, des Etats-Unis, à Fort Worth (US), administrateur, Président de la direction / CEO, signature collective à deux. Glanzmann Thomas Heinrich, de Hasle bei Burgdorf, à Wilen bei Wollerau, administrateur, signature collective à deux. Maw Scott Harlan, des Etats-Unis, à Seattle (US), administrateur, signature collective à deux. May Karen, des Etats-Unis, à Lincolnshire (US), administrateur, signature collective à deux. Pöschel Ines, de Winterthur, à Zürich, administrateur, signature collective à deux. Spälti Dieter Paul, de Hettlingen, à Nuerensdorf, administrateur, signature collective à deux. Bedward Royce Richard, des Etats-Unis, à Fort Worth (US), secrétaire hors conseil, signature collective à deux. Attias Laurent, des Etats-Unis, à Fort Worth (US), directeur, signature collective à deux. Bell Ian Howard, d'Angleterre, à Genève, directeur, signature collective à deux. Onuscheck John Michael, des Etats-Unis, à Fort Worth (US), directeur, signature collective à deux. Auffret Sandrine Laurence, de France, à Divonne-les-Bains (FR), signature collective à deux. Bajpai Vikramaditya, d'Inde, à Riehen, signature collective à deux. Baldock Lesley Jane, d'Angleterre, à Genève, signature collective à deux. Bohmann Christine, d'Allemagne, à Fort Worth (US), signature collective à deux. Colombo Franco, d'Italie, à Paradiso, signature collective à deux. Hjalber Jan Olof, de Suède, à Genève, signature collective à deux. Hudnall Thomas Ruben, des Etats-Unis, à Colleyville (US), signature collective à deux. Lutz Manuel Hubertus Maria Felix, des Pays-Bas, à Meyrin, signature collective à deux. McCracken Merrick, des Etats-Unis, à Dallas (US), signature collective à deux. Prouvoyeur Vincent Arnaud, de France, à Genève, signature collective à deux. Russell Dominic James, d'Angleterre, à Southlake (US), signature collective à deux. Zimmermann Brice Arnaud, de France, à Basel, signature collective à deux.

SHAB: 71 vom 11.04.2019
Tagesregister: 2091 vom 09.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004608462
Kantone: FR

SHAB01.02.2019
|
Alcon AG

Mutation Alcon AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Kapital neu

Alcon AG, à Fribourg, CHE-234.781.164 (FOSC du 28.12.2018, p. 0/1004532233). Dorénavant, les inscriptions seront effectuées en français.

But nouveau:
La Société a pour but d'acquérir, de détenir, de gérer, et d'aliéner des participations directes et indirectes dans des entreprises de toute nature, en particulier des entreprises actives dans le domaine de la santé, des équipements médicaux, de la biologie, la chimie, la physique, de l'informatique ou d'autres domaines liés, en Suisse ou à l'étranger. La Société peut constituer des entreprises de toute nature en Suisse ou à l'étranger, détenir des parts dans ces entreprises et en assumer la gestion. La Société peut aquérir, mettre en gage, exploiter et aliéner des immeubles et des droits immatiériels en Suisse et à l'étranger. La Société peut accorder des prêts, des garanties et toutes autres sortes de financements ou de sûretés pour des sociétés du Groupe, ainsi qu'emprunter et investir des fonds dans les marchés des devises et des capitaux. La Société peut s'engager dans des activités ou des transactions de toute autre nature et peut prendre toutes mesures qui lui apparaissent adéquates à promouvoir le but de la Société ou qui sont liées à celui-ci. Dans la poursuite de son but, la Société aspire à la création de valeur durable.

Augmentation ordinaire:
Capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 19'548'000 par l'émission de 486'200'000 actions nominatives de CHF 0.04, entièrement libérées en espèces.

Capital-actions nouveau:
CHF 19'548'000, entièrement libéré, divisé en 488'700'000 actions nominatives de CHF 0.04.

Organe de publication:
FOSC.

Communication aux actionnaires nouveau:
FOSC. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 29.01.2019. Pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 29.01.2019.

Personnes inscrites:
Kirsch Harry Werner, d'Allemagne, à Therwil, administrateur président, signature collective à deux. Klinger Shannon Thyme, des Etats-Unis, à Basel, administrateur secrétaire, signature collective à deux. Baert Steven Lodewijk Margareta, de Belgique, à Reinach BL, administrateur, signature collective à deux. Ball Francis Michael, des Etats-Unis, à Naples (US), administrateur, signature collective à deux. Eichhorn Felix Hermann, de et à Basel, signature collective à deux. Emery Jean-Baptiste, d'Estavayer, à Fribourg, signature collective à deux. Guertin Marie-Claude, du Canada, à Faoug, signature collective à deux. Kamffer Robert Edward, de l'Afrique du Sud, à Fribourg, signature collective à deux. Rehm Christian Jakob, de Ilanz/Glion, à Muttenz, signature collective à deux. Roth Pellanda Katja Nicole, de et à Basel, signature collective à deux. Saiz Garcia Maria, d'Espagne, à Genève, signature collective à deux. Scholtz Duncan Myndert Lacock, du Royaume-Uni, à Olten, signature collective à deux. Schreiner Peter Christian, de Visp, à Muttenz, signature collective à deux. St. John Lawrence André Ludwig, de Frutigen, à Marly, signature collective à deux. Weiss Daniel Andreas, de Basel, à Biel-Benken, signature collective à deux. PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), à Genève, organe de révision.

SHAB: 22 vom 01.02.2019
Tagesregister: 636 vom 30.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004556416
Kantone: FR

SHAB28.12.2018
|
Alcon AG

Mutation Alcon AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Alcon AG, in Fribourg, CHE-234.781.164 (SHAB vom 01.10.2018, s. 0/1004466037).

Neu eingetragene Personen:
Emery Jean-Baptiste, von Estavayer, in Fribourg, Kollektivunterschrift zu zweien; Guertin Marie-Claude, kanadische Staatsangehörige, in Faoug, Kollektivunterschrift zu zweien; Kamffer Robert Edward, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Fribourg, Kollektivunterschrift zu zweien; Saiz Garcia Maria, spanische Staatsangehörige, in Genève, Kollektivunterschrift zu zweien; Scholtz Duncan Myndert Lacock, britischer Staatsangehöriger, in Olten, Kollektivunterschrift zu zweien; St. John Lawrence André Ludwig, von Frutigen, in Marly, Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 251 vom 28.12.2018
Tagesregister: 6836 vom 21.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004532233
Kantone: FR

SHAB01.10.2018
|
Alcon AG

Mutation Alcon AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Alcon AG, in Fribourg, CHE-234.781.164 (SHAB vom 26.09.2018, s. 0/1004463125). Berichtigung der Eintragung Nr. 5014 vom 21.09.2018 (SHAB vom 26.09.2018, Id 1004463125): die korrekte Adresse lautet: Rue Louis-d'Affry 6, 1701 (und nicht 1700) Fribourg.

SHAB: 189 vom 01.10.2018
Tagesregister: 5105 vom 26.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004466037
Kantone: FR

Unsere Produkte
Lixt Monitoring Lixt Monitoring

Monitoring

Sie suchen Informationen über Firmen, Management, Ausschreibungen und Marken? Jetzt kostenlos.
Lixt Inkasso Lixt Inkasso

Inkasso

Zahlen Ihre Kunden die Rechnungen nicht? Wir helfen Ihnen, dass Sie zu Ihrem Geld kommen.
Lixt Factoring Lixt Factoring

Factoring

Leiden Sie an langen Zahlungsfristen? Wir zahlen Ihre Kundenrechnungen innert 2 Tagen.
Lixt
Gratis

Lixt
Starter-Paket

Inklusive Zugriff auf alle Hintergrundinformationen, Marken und 2 Überwachungen.

Kostenlos anmelden